Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Marengo County

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Registered Historic Places im Marengo County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im Marengo County in Alabama auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Aktuelle Einträge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Lfd. Nr. Name Bild Datum der Eintragung Adresse/Lage Ort ID-Nr. Beschreibung
1 Allen Grove 7. Juli 1994 Co. Rd. 1, S of Old Spring Hill Old Spring Hill 94000689
2 Altwood 13. Juli 1993 W of Marengo Co. Rd. 51, S of jct. with Co. Rd. 54 Faunsdale 93000598
3 Ashe Cottage 19. Okt. 1978 307 N. Commissioners Ave. Demopolis 78000502
4 Bluff Hall 28. Juli 1970 405 N. Commissioners Ave. Demopolis 70000105
5 C. S. Golden House 31. Aug. 2000 540 Seventh Ave. Thomaston 00001029
6 Cedar Crest 5. Aug. 1993 E. side Marengo Co. Rd. 51, .5 mi. S. of Co. Rd. 54 Faunsdale 93000763
7 Cedar Grove Plantation 13. Juli 1993 Marengo Co. Rd. E of jct. with AL 25 Faunsdale 93000599
8 Cedar Haven 13. Juli 1993 Marengo Co. Rd. 61 SE of jct. with AL 25 Faunsdale 93000600
9 Confederate Park 29. Okt. 1975 Bounded by Main, Capitol, Walnut, and Washington Sts. Demopolis 75000319
10 Cuba Plantation 13. Juli 1993 Marengo Co. Rd. 54 W of jct. with AL 25 Faunsdale 93000601
11 Curtis House 11. Apr. 1977 510 N. Main Demopolis 77000214
12 Demopolis Historic Business District 25. Okt. 1979 Roughly bounded by Capital and Franklin Sts., Desnanette and Cedar Aves. Demopolis 79000391
13 Demopolis Public School 28. Okt. 1983 601 S. Main Ave. Demopolis 83003453
14 Faunsdale Plantation 13. Juli 1993 Marengo Co. Rd. 54 just W of jct. with AL 25 Faunsdale 93000602
15 Foscue-Whitfield House 21. Jan. 1974 W of Demopolis on U.S. 80 Demopolis 74000423
16 Gaineswood 5. Jan. 1972 805 S. Cedar St. Demopolis 72000167 Hat außerdem den Status eines National Historic Landmarks[1]
17 Glover Mausoleum 21. Jan. 1974 Riverside Cemetery Demopolis 74000424
18 Half-Chance Bridge 14. Sep. 1972 SR 39 over the Chickasaw Bogue Creek Dayton 72000166
19 Jefferson Historic District 13. Nov. 1976 AL 28 Jefferson 76000342
20 Lyon-Lamar House 21. Jan. 1974 102 S. Main Ave. Demopolis 74000425
21 Old Courthouse 18. Jan. 1974 300 W. Cahaba Ave. Linden 74000426
22 Patrick Farrish House 31. Aug. 2000 177 East St. Thomaston 00001026
23 Roseland Plantation 20. Jan. 1994 Co. Rd. 54, about 2 mi. SE of Faunsdale. Faunsdale 93001476
24 Thomaston Central Historic District 14. Sep. 2000 Roughly bounded by Chestnut St., Sixth Ave., Seventh Ave., Short St. and CSX RR. Thomaston 00001023
25 Thomaston Colored Institute 31. Aug. 2000 1120 Seventh Ave. Thomaston 00001024
26 US Post Office 28. Juli 1984 100 W. Capitol St. Demopolis 84000657
27 White Bluff 25. Aug. 1970 Arch St. Demopolis 70000106
28 William Poole House 7. Juli 1994 Jct. of AL 25 and Palmetto Rd. Dayton 94000687

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Listing of National Historic Landmarks by State: Alabama. National Park Service, abgerufen am 13. April 2020.